Chambre de commerce de Ville DГ©gelis

Address: 352 3e Avenue, Ste Rose Du Degelis, QC G0L 1H0

Chambre de commerce de Ville DГ©gelis (Corporation# 8869) is a federal corporation entity registered with Corporations Canada. The incorporation date is April 9, 1959.

Corporation Overview

Corporation ID 8869
Corporation Name Chambre de commerce de Ville DГ©gelis
Registered Office Address 352 3e Avenue
Ste Rose Du Degelis
QC G0L 1H0
Incorporation Date 1959-04-09
Dissolution Date 2011-02-10
Corporation Status Dissolved / Dissoute
Number of Directors 13 - 13

Directors

Director Name Director Address
YVON C. DUMONT 353 3E AVE., STE ROSE DU DEGELIS QC G0L 1H0, Canada
MONIQUE OUELLET 353 3E AVE., STE ROSE DU DEGELIS QC G0L 1H0, Canada
SYLVAIN THERIAULT 353 3E AVE., STE ROSE DU DEGELIS QC G0L 1H0, Canada
MARTIN RAYMOND 353 3E AVE., STE ROSE DU DEGELIS QC G0L 1H0, Canada
DENIS PARENT 353 3E AVE., STE ROSE DU DEGELIS QC G0L 1H0, Canada
ALAIN THERIAULT 353 3E AVE., STE ROSE DU DEGELIS QC G0L 1H0, Canada
CHANTAL DAMBOISE 353 3E AVE., STE ROSE DU DEGELIS QC G0L 1H0, Canada
EDITH GRONDIN 353 3E AVE., STE ROSE DU DEGELIS QC G0L 1H0, Canada
MARC-A. DE LAUNIERE 353 3E AVE., STE ROSE DU DEGELIS QC G0L 1H0, Canada
EMILIEN BEAULIEU 353 3E AVE., STE ROSE DU DEGELIS QC G0L 1H0, Canada
MAURICE PEDNAULT 353 3E AVE., STE ROSE DU DEGELIS QC G0L 1H0, Canada
RAYMOND PERRON 353 3E AVE., STE ROSE DU DEGELIS QC G0L 1H0, Canada
PIERRE MORIN 353 3E AVE., STE ROSE DU DEGELIS QC G0L 1H0, Canada

Corporation History

Type Effective Date Expiry Date Detail
Act 1959-04-09 current Boards of Trade Act - Part I (BOTA - Part I)
Loi sur les chambres de commerce - partie I (LCH - Partie I)
Act 1959-04-08 1959-04-09 Boards of Trade Act - Part I (BOTA - Part I)
Loi sur les chambres de commerce - partie I (LCH - Partie I)
Address 1959-04-09 current 352 3e Avenue, Ste Rose Du Degelis, QC G0L 1H0
Name 1994-02-04 current Chambre de commerce de Ville DГ©gelis
Name 1959-04-09 1994-02-04 LA CHAMBRE DE COMMERCE SENIOR DE STE-ROSE-DU-DEGELE
Status 2011-02-10 current Dissolved / Dissoute
Status 1959-04-09 2011-02-10 Active / Actif

Activities

Date Activity Details
2011-02-10 Dissolution
1959-04-09 Incorporation / Constitution en sociГ©tГ©

Annual Returns Filings

Year Annual Meeting Date Corporation Type
1997 1992-05-25
1996 1992-05-25

Office Location

Address 352 3E AVENUE
City STE ROSE DU DEGELIS
Province QC
Postal Code G0L 1H0
Country Canada

Corporations in the same postal code

Corporation Name Office Address Incorporation
Encadrement New Art Framing Inc. 8 Industriel, Degelis, QC G0L 1H0 1995-09-19
3153177 Canada Inc. 50 Rue Industrielle, Degelis, QC G0L 1H0 1995-06-05
2966191 Canada Inc. 465-b Avenue Principale, Degelis, QC G0L 1H0 1993-10-25
CroisiÈres TÉmiwaska Inc. 210 Route 295, C P 580, Degelis, QC G0L 1H0 1992-11-20
P.m.p. Plastics Inc. 1208 Route 185 Sud, Degelis, QC G0L 1H0 1989-11-15
Lingerie Jean-guy Lachance Inc. 465-b Rue Principale, Degelis, QC G0L 1H0 1984-12-12
Chantiers Temis Ltee Rang Turcotte, Degelis, QC G0L 1H0 1984-05-09
Degelis Construction Inc. 807 7e Rue, Degelis, Cte Temiscouata, QC G0L 1H0 1983-08-30
Les Entreprises De Liquidation Degelis Inc. 325 Garre Beaulieu, Degelis Cte Temiscouata, QC G0L 1H0 1983-06-03
Garage Gauthier Landry Et Fils Inc. 1207 Rte Transcanadienne, Ville Degelis, QC G0L 1H0 1983-04-26
Find all corporations in postal code G0L1H0

Corporation Directors

Name Address
YVON C. DUMONT 353 3E AVE., STE ROSE DU DEGELIS QC G0L 1H0, Canada
MONIQUE OUELLET 353 3E AVE., STE ROSE DU DEGELIS QC G0L 1H0, Canada
SYLVAIN THERIAULT 353 3E AVE., STE ROSE DU DEGELIS QC G0L 1H0, Canada
MARTIN RAYMOND 353 3E AVE., STE ROSE DU DEGELIS QC G0L 1H0, Canada
DENIS PARENT 353 3E AVE., STE ROSE DU DEGELIS QC G0L 1H0, Canada
ALAIN THERIAULT 353 3E AVE., STE ROSE DU DEGELIS QC G0L 1H0, Canada
CHANTAL DAMBOISE 353 3E AVE., STE ROSE DU DEGELIS QC G0L 1H0, Canada
EDITH GRONDIN 353 3E AVE., STE ROSE DU DEGELIS QC G0L 1H0, Canada
MARC-A. DE LAUNIERE 353 3E AVE., STE ROSE DU DEGELIS QC G0L 1H0, Canada
EMILIEN BEAULIEU 353 3E AVE., STE ROSE DU DEGELIS QC G0L 1H0, Canada
MAURICE PEDNAULT 353 3E AVE., STE ROSE DU DEGELIS QC G0L 1H0, Canada
RAYMOND PERRON 353 3E AVE., STE ROSE DU DEGELIS QC G0L 1H0, Canada
PIERRE MORIN 353 3E AVE., STE ROSE DU DEGELIS QC G0L 1H0, Canada

Competitor

Search similar business entities

City STE ROSE DU DEGELIS
Post Code G0L1H0

Similar businesses

Corporation Name Office Address Incorporation
Chamber of Marine Commerce 300 Sparks Street, Suite 340, Place De Ville, Podium Building, Ottawa, ON K1R 7S3 1959-11-02
Chamber of Commerce of The Town Gatineau Noaddressline, Nocity, QC 1956-07-24
Chambre De Commerce Du TГ©miscouata 201-3 Rue De L'hotel-de-ville, Temiscouata-sur-le-lac, QC G0L 1X0 1983-03-11
Chambre De Commerce TГ©mis-accord 7-b Rue Des Oblats Nord, Ville-marie, QC J9V 1H9 1971-03-24
Chambre De Commerce Ville Les Saules 1661 Carre Ader, Ville Les Saules, QC 1966-03-23
Chambre De Commerce De Ville Saint-michel 44 Boul D'argenson, Repentigny, QC J6A 3W4 1950-03-20
Chambre De Commerce De Ville St-remi 17 Rue Prud'homme, Ville St-remi, QC 1963-08-12
Chambre De Commerce Et D'industrie Royal-roussillon 1068 Rue Union, Ville Ste-catherine, QC J5C 1B3 2006-10-30
Chambre De Commerce De Ville D'anjou 500 Place D'armes, Bur. 3030, Montreal, QC H2Y 2W2 1986-12-11
The Chamber of Commerce Town of Mont Royal 4480 Cote De Liesse, Suite 110, Mont Royal, QC H4N 2R1 1990-11-02

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on Chambre de commerce de Ville DГ©gelis.

Dataset Information

Data Provider Corporations Canada
Jurisdiction Canada

This dataset includes 999 thousand corporation entities registered with Corporations Canada, a division of Innovation, Science and Economic Development Canada. Each corporation is registered with corporation number, corporate name, office address, current status, directors, annual filling dates, etc.