REGROUPEMENT DES ORGANISMES CANADO-HAITIEN POUR LE DÉVELOPPEMENT (ROCAHD)

Address: 801 Sherbrooke Est, Suite 400, Montreal, QC H2L 1K7

REGROUPEMENT DES ORGANISMES CANADO-HAITIEN POUR LE DÉVELOPPEMENT (ROCAHD) (Corporation# 3052419) is a federal corporation entity registered with Corporations Canada. The incorporation date is July 18, 1994.

Corporation Overview

Corporation ID 3052419
Business Number 898589064
Corporation Name REGROUPEMENT DES ORGANISMES CANADO-HAITIEN POUR LE DÉVELOPPEMENT (ROCAHD)
Registered Office Address 801 Sherbrooke Est
Suite 400
Montreal
QC H2L 1K7
Incorporation Date 1994-07-18
Dissolution Date 2016-06-30
Corporation Status Dissolved / Dissoute
Number of Directors 1 - 11

Directors

Director Name Director Address
WANEX ZÉPHYR 674 JOSEPH-VAILLANCOURT, LACHENAIE QC J6V 1P6, Canada
DENISE GAGNON 565 BLVD CREMAZIE, BUREAU 12100, MONTREAL QC H2M 2W3, Canada
ALIX JEAN 8833 BLVD ST. MICHEL, MONTREAL QC H1Z 2G3, Canada
FRANTZ LAFONTANT 415 RUE ST-ROCH, BUREAU 6 ETAGE 1, MONTREAL QC H3N 1K2, Canada
GOLDY DELCY 4456 RUE ELGIN, APP. 1, PIERREFONDS QC H9H 1V2, Canada
PIERRE THEAGENE 12201 6E AVENUE, MONTREAL QC H1C 1W8, Canada
PHILOMENE CAYEMITTE 10925 ST-JULIEN, MONTREAL NORD QC H1H 3Y4, Canada
EDITH DUTERVILLE 1350 RUE GADBOIS, SAINT-HUBERT QC J4T 3P2, Canada
ANDREE FORTIN 161 BUTTERNUT, MONTREAL QC H4C 3E6, Canada

Corporation History

Type Effective Date Expiry Date Detail
Act 1994-07-18 current Canada Corporations Act - Part II (CCA - Part II)
Loi sur les corporations canadiennes - partie II (LCC - Partie II)
Act 1994-07-17 1994-07-18 Canada Corporations Act - Part II (CCA - Part II)
Loi sur les corporations canadiennes - partie II (LCC - Partie II)
Address 2008-03-31 current 801 Sherbrooke Est, Suite 400, Montreal, QC H2L 1K7
Address 1994-07-18 2008-03-31 801 Sherbrooke Est, Suite 400, Montreal, QC H2L 1K7
Name 1994-07-18 current REGROUPEMENT DES ORGANISMES CANADO-HAITIEN POUR LE DÉVELOPPEMENT (ROCAHD)
Status 2016-06-30 current Dissolved / Dissoute
Status 2016-02-01 2016-06-30 Active - Dissolution Pending (Non-compliance) / Actif - Dissolution en cours (Non-conformitГ©)
Status 1994-07-18 2016-02-01 Active / Actif

Activities

Date Activity Details
2016-06-30 Dissolution Section: 222
2001-10-19 Ordinary By-Laws Filing / DГ©pГґt de rГЁglement ordinaire
2000-08-02 Amendment / Modification
1999-06-29 Ordinary By-Laws Filing / DГ©pГґt de rГЁglement ordinaire
1994-07-18 Incorporation / Constitution en sociГ©tГ©

Annual Returns Filings

Year Annual Meeting Date Corporation Type
2011 2010-11-27
2010 2009-11-14
2008 2007-09-29

Office Location

Address 801 SHERBROOKE EST
City MONTREAL
Province QC
Postal Code H2L 1K7
Country Canada

Corporations in the same location

Corporation Name Office Address Incorporation
Les Immeubles Parc Lafontaine Ltee. 801 Sherbrooke Est, Bu. 1100, Montreal, QC H2L 1K7 1981-01-13
Les Developpements Immocondel Ltee 801 Sherbrooke Est, Bur. 1100, Montreal, QC H2L 1K7 1981-09-28
120738 Canada Inc. 801 Sherbrooke Est, Bur. 1100, Montreal, QC H2L 1K7 1983-01-13
N.s. Inter, Societe Conseil En Gestion De Projets Internationaux Inc. 801 Sherbrooke Est, Bur 513, Montreal, QC H2L 1K7 1983-01-31
3137503 Canada Inc. 801 Sherbrooke Est, Bur 609, Montreal, QC H2L 1K7 1995-04-12
Location Immocondel Inc. 801 Sherbrooke Est, Bur. 1100, Montreal, QC H2L 1K7 1982-01-25
Le Centre De Ski Roussillon Inc. 801 Sherbrooke Est, Bur 1100, Montreal, QC H2L 1K7 1984-08-21

Corporations in the same postal code

Corporation Name Office Address Incorporation
3648273 Canada Inc. 801 Sherbrooke St East, 10th Floor, Montreal, QC H2L 1K7 1999-08-06

Corporations in the same postal prefix

Corporation Name Office Address Incorporation
Simmunome Inc. 211-825 Boulevard Rene-levesque Est, Montreal, QC H2L 0A1 2017-02-02
2954192 Canada Inc. 825 Boul. RenÉ-lÉvesques Est, App. 708, MontrÉal, QC H2L 0A1 1993-09-14
10954535 Canada Corporation 825, Rene-levesque Est, Montreal, QC H2L 0A1 2018-08-21
Gestions Genicourt Inc. 801 De La Commune, # 608, Montreal, QC H2L 0A3 1987-05-13
Mdi Multi Design International Inc. 502-801 Rue De La Commune Est, Montreal, QC H2L 0A3
Rndfood Consultants Incorporated 355 St-hubert, Montreal, QC H2L 0A5 2010-02-01
Fdl Construction and Renovations Inc. 1795 Berri Rue, 625, Montreal, QC H2L 0B1 2020-11-29
11640348 Canada Inc. 1785 Rue Berri, MontrГ©al, QC H2L 0B1 2019-09-22
Nvcore Inc. 308-801 Sherbrooke East, MontrГ©al, QC H2L 0B7 2019-10-11
One Undone Multi Medium Inc. 801 Rue Sherbrooke Est, Suite 307, MontrГ©al, QC H2L 0B7 2019-09-17
Find all corporations in postal code H2L

Corporation Directors

Name Address
WANEX ZÉPHYR 674 JOSEPH-VAILLANCOURT, LACHENAIE QC J6V 1P6, Canada
DENISE GAGNON 565 BLVD CREMAZIE, BUREAU 12100, MONTREAL QC H2M 2W3, Canada
ALIX JEAN 8833 BLVD ST. MICHEL, MONTREAL QC H1Z 2G3, Canada
FRANTZ LAFONTANT 415 RUE ST-ROCH, BUREAU 6 ETAGE 1, MONTREAL QC H3N 1K2, Canada
GOLDY DELCY 4456 RUE ELGIN, APP. 1, PIERREFONDS QC H9H 1V2, Canada
PIERRE THEAGENE 12201 6E AVENUE, MONTREAL QC H1C 1W8, Canada
PHILOMENE CAYEMITTE 10925 ST-JULIEN, MONTREAL NORD QC H1H 3Y4, Canada
EDITH DUTERVILLE 1350 RUE GADBOIS, SAINT-HUBERT QC J4T 3P2, Canada
ANDREE FORTIN 161 BUTTERNUT, MONTREAL QC H4C 3E6, Canada

Competitor

Search similar business entities

City MONTREAL
Post Code H2L 1K7

Similar businesses

Corporation Name Office Address Incorporation
Regroupement Social Canado-haitien 637-1500 Bank Street, Ottawa, ON K1H 1B8 2010-03-17
Foundation for Development Canado-vietnam (f.d.ca-vi) 8621 23e Avenue, Montreal, QC H1Z 3Y3 1997-07-21
Regroupement Pour La SolidaritГ© Et Le DГ©veloppement - BГЁni So 702 Rue Routhier, Quebec, QC G1X 3J9 2006-05-23
Agence Canado-djiboutienne Pour La Promotion Et Le DÉveloppement Socio-Économique 64 Meaghan Pvt, Ottawa, ON K1G 5T2 2009-02-05
La Fondation Canado-haÏtienne Pour L'Éducation Et Le DÉveloppement (foched) 2063 Holmes, Apt. 5, St-hubert, QC J4T 1R7 2003-10-21
Groupe Haitien Pour La PrÉvention Du Sida 8000 8e Avenue, Montreal, QC H1Z 2V9 1989-11-24
S.n.d.,regroupement Favorisant L'Éducation Au DÉveloppement International Équitable 942 Rue Sainte-genevieve, Trois Riviere, QC G9A 3X6 1996-12-19
Institution En Formation Et En Gestion Pour Organismes Et SociГ©tГ©s (ifgos) 550 Ch. Saint-lГ©on, Rimouski, QC G5N 1W8 2019-06-04
Regroupement Pour L'unitÉ Ethnique Du Canada 753 Allion, Ville Lasalle, QC H8P 2C8 2005-02-04
Institut Pour La Paix Et Le DÉveloppement Pour Le Moyen-orient 1501 Mcgill College Ave., 26th Fl., Montreal, QC H3A 3N9 1989-07-05

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on REGROUPEMENT DES ORGANISMES CANADO-HAITIEN POUR LE DÉVELOPPEMENT (ROCAHD).

Dataset Information

Data Provider Corporations Canada
Jurisdiction Canada

This dataset includes 999 thousand corporation entities registered with Corporations Canada, a division of Innovation, Science and Economic Development Canada. Each corporation is registered with corporation number, corporate name, office address, current status, directors, annual filling dates, etc.