L'INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DU QUÉBEC
URBAN DEVELOPMENT INSTITUTE OF QUEBEC

Address: 2115-1010 Rue De La GauchetiГЁre Ouest, MontrГ©al, QC H3B 2N2

L'INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DU QUÉBEC (Corporation# 2219409) is a federal corporation entity registered with Corporations Canada. The incorporation date is August 25, 1987.

Corporation Overview

Corporation ID 2219409
Business Number 103341889
Corporation Name L'INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DU QUÉBEC
URBAN DEVELOPMENT INSTITUTE OF QUEBEC
Registered Office Address 2115-1010 Rue De La GauchetiГЁre Ouest
MontrГ©al
QC H3B 2N2
Incorporation Date 1987-08-25
Corporation Status Active / Actif
Number of Directors 10 - 45

Directors

Director Name Director Address
Roger Plamondon 500-16766 RTE Trans-Canadienne, Kirkland QC H9H 4M7, Canada
Yves Godin 1600-1100 boul. René-Lévesque O., Montréal QC H3B 4N4, Canada
Martin Raymond 1800 Avenue McGill College, Bureau 1900, Montréal QC H3A 3J6, Canada
Jean-Marc Fournier 1010 rue de la Gauchetière Ouest, Montréal QC H3B 2N2, Canada
Laurence Vincent 1020 Rue William, Montréal QC H3C 1P6, Canada
Joe Argento 255-1981, avenue McGill Collège, Montréal QC H3A 3A8, Canada
Stéphane Coté 810-407 Rue McGill, Montréal QC H2Y 2G3, Canada
Luc Fortin 7600, rue Viau, RDC113, Montréal QC H1S 2P3, Canada
André Fortin 295, rue Montfort, Lévis QC G6W 3L8, Canada
Brett Miller 900-2000 rue Peel, Montréal QC H3A 2W5, Canada
Nathalie Rousseau 1001 Rue du Square-Victoria, Montréal QC H2Z 0A4, Canada
James Papadimitriou 2500-1000, de la Gauchetière Ouest, Montréal QC H3B 0A2, Canada
SYLVAIN CHARPENTIER 75 BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL QC H2L 1A4, Canada
LAURENT BENARROUS 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, BUREAU 1950, MONTREAL QC H3A 3H3, Canada
Brian Salpeter 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Bureau 400, Montréal QC H3B 2S2, Canada
Sylvie Samson 1501, avenue McGill College, 26e étage, Montréal QC H3A 3N9, Canada
Jean Laramée 1600-3400 boul De Maisonneuve O., Montréal QC H3Z 3B8, Canada
Anthony Arquin 1501, avenue McGill College, 26e étage, Montréal QC H3A 3N9, Canada
France Rodrigue 1000-2525 Boul. Laurier, Quebec QC G1V 4L2, Canada
Irene Peng 503-1425 Rene-Levesque Ouest, Montréal QC H3G 1T7, Canada
Yves-André Godon 55-1155 rue Metclafe, Montréal QC H3B 2V6, Canada
Josée Bérubé 700-276 Rue Saint-Jacques, Montréal QC H2Y 1N3, Canada
Luc Gratton 1000 Rue de la Gauchetière Ouest, Suite 3700, Montréal QC H3B 4W5, Canada

Corporation History

Type Effective Date Expiry Date Detail
Act 2014-09-24 current Canada Not-for-profit Corporations Act (NFP Act)
Loi canadienne sur les organisations Г  but non lucratif (Loi BNL)
Act 1987-08-25 2014-09-24 Canada Corporations Act - Part II (CCA - Part II)
Loi sur les corporations canadiennes - partie II (LCC - Partie II)
Act 1987-08-24 1987-08-25 Canada Corporations Act - Part II (CCA - Part II)
Loi sur les corporations canadiennes - partie II (LCC - Partie II)
Address 2019-09-27 current 2115-1010 Rue De La GauchetiГЁre Ouest, MontrГ©al, QC H3B 2N2
Address 2017-10-24 2019-09-27 2115-1010 Rue De La GauchetiГЁre Ouest, Montreal, QC H3B 2N2
Address 2014-09-24 2017-10-24 1010 Rue De La Gauchetiere Ouest, Bureau 2115, Montreal, QC H3B 2N2
Address 2014-07-25 2014-09-24 800 Place Victoria, Bureau 3700, MontrÉal, QC H4Z 1E9
Address 2011-03-31 2014-07-25 800 Place Victoria, Tour De La Bourse, Bur 3700, Cp 242, MontrÉal, QC H4Z 1E9
Address 2007-03-31 2011-03-31 800 Place Victoria, Ste. 3400, MontrÉal, QC H4Z 1E9
Address 1987-08-25 2007-03-31 800 Place Victoria, Suite 3400 Po Box 242, Montreal, QC H4Z 1E9
Name 2014-09-24 current L'INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DU QUÉBEC
Name 2014-09-24 current URBAN DEVELOPMENT INSTITUTE OF QUEBEC
Name 1987-08-25 2014-09-24 URBAN DEVELOPMENT INSTITUTE OF QUEBEC
Name 1987-08-25 2014-09-24 L'INSTITUT DE DEVELOPPEMENT URBAIN DU QUEBEC
Status 2014-09-24 current Active / Actif
Status 1987-08-25 2014-09-24 Active / Actif

Activities

Date Activity Details
2014-09-24 Continuance (transition) / Prorogation (transition) Jurisdiction: Canada Corporations Act - Part II (CCA-II) / Loi sur les corporations canadiennes, partie 2 (LCC-Partie 2)
2003-12-19 Ordinary By-Laws Filing / DГ©pГґt de rГЁglement ordinaire
1999-02-07 Ordinary By-Laws Filing / DГ©pГґt de rГЁglement ordinaire
1987-08-25 Incorporation / Constitution en sociГ©tГ©

Annual Returns Filings

Year Annual Meeting Date Corporation Type
2020 2020-06-16 Non-Soliciting
N'ayant pas recours Г  la sollicitation
2019 2019-06-18 Non-Soliciting
N'ayant pas recours Г  la sollicitation
2018 2018-06-07 Non-Soliciting
N'ayant pas recours Г  la sollicitation
2017 2017-06-08 Non-Soliciting
N'ayant pas recours Г  la sollicitation

Office Location

Address 2115-1010 rue de la GauchetiГЁre Ouest
City MontrГ©al
Province QC
Postal Code H3B 2N2
Country Canada

Corporations in the same postal code

Corporation Name Office Address Incorporation
Evotiontech Inc. 950-1010, De La GauchetiГЁre Street West, Montreal, QC H3B 2N2 2020-11-19
Cannabis Quality Assurance (cqa) Inc. 950-1010 Rue De La GauchetiГЁre West, MontrГ©al, QC H3B 2N2 2019-03-06
Evofun Inc. 950-1010 Rue De La GauchetiГЁre Ouest, MontrГ©al, QC H3B 2N2 2019-01-25
10863335 Canada Inc. 1020-1010 De La GauchetiГЁre Street West, MontrГ©al, QC H3B 2N2 2018-06-28
Digital Nomad Analytics Inc. 200-1010 Rue De La GauchetiГЁre O, Montreal, QC H3B 2N2 2017-05-04
9993819 Canada Inc. 1010 De La Gauchetiere W., Suite 1315, Montreal (ville-marie), QC H3B 2N2 2016-11-22
9992049 Canada Inc. 1020-1010 Rue De La GauchetiГЁre O, MontrГ©al, QC H3B 2N2 2016-11-21
9727744 Canada Inc. 1020-1010 De La GauchetiГЁre St W., MontrГ©al, QC H3B 2N2 2016-04-27
9155830 Canada Inc. 1010, De La GauchetiГЁre Street West, Suite 1020, Montreal, QC H3B 2N2 2015-01-16
9062467 Canada Inc. 1010 De La GauchetiГЁre W, Suite 1230, MontrГ©al, QC H3B 2N2 2014-10-24
Find all corporations in postal code H3B 2N2

Corporation Directors

Name Address
Roger Plamondon 500-16766 RTE Trans-Canadienne, Kirkland QC H9H 4M7, Canada
Yves Godin 1600-1100 boul. René-Lévesque O., Montréal QC H3B 4N4, Canada
Martin Raymond 1800 Avenue McGill College, Bureau 1900, Montréal QC H3A 3J6, Canada
Jean-Marc Fournier 1010 rue de la Gauchetière Ouest, Montréal QC H3B 2N2, Canada
Laurence Vincent 1020 Rue William, Montréal QC H3C 1P6, Canada
Joe Argento 255-1981, avenue McGill Collège, Montréal QC H3A 3A8, Canada
Stéphane Coté 810-407 Rue McGill, Montréal QC H2Y 2G3, Canada
Luc Fortin 7600, rue Viau, RDC113, Montréal QC H1S 2P3, Canada
André Fortin 295, rue Montfort, Lévis QC G6W 3L8, Canada
Brett Miller 900-2000 rue Peel, Montréal QC H3A 2W5, Canada
Nathalie Rousseau 1001 Rue du Square-Victoria, Montréal QC H2Z 0A4, Canada
James Papadimitriou 2500-1000, de la Gauchetière Ouest, Montréal QC H3B 0A2, Canada
SYLVAIN CHARPENTIER 75 BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL QC H2L 1A4, Canada
LAURENT BENARROUS 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, BUREAU 1950, MONTREAL QC H3A 3H3, Canada
Brian Salpeter 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Bureau 400, Montréal QC H3B 2S2, Canada
Sylvie Samson 1501, avenue McGill College, 26e étage, Montréal QC H3A 3N9, Canada
Jean Laramée 1600-3400 boul De Maisonneuve O., Montréal QC H3Z 3B8, Canada
Anthony Arquin 1501, avenue McGill College, 26e étage, Montréal QC H3A 3N9, Canada
France Rodrigue 1000-2525 Boul. Laurier, Quebec QC G1V 4L2, Canada
Irene Peng 503-1425 Rene-Levesque Ouest, Montréal QC H3G 1T7, Canada
Yves-André Godon 55-1155 rue Metclafe, Montréal QC H3B 2V6, Canada
Josée Bérubé 700-276 Rue Saint-Jacques, Montréal QC H2Y 1N3, Canada
Luc Gratton 1000 Rue de la Gauchetière Ouest, Suite 3700, Montréal QC H3B 4W5, Canada

Competitor

Search similar business entities

City MontrГ©al
Post Code H3B 2N2

Similar businesses

Corporation Name Office Address Incorporation
2m Urban Development Inc. 825, Querbes Avenue, Suite 201, Montreal, QC H2V 3X1 2019-11-26
Les Consultants Jacques Dagenais Et Associes Limitee Urban Quebec Urbain, Urban Quebec Urbain, QC 1980-03-13
Institut International De DÉveloppement Integral - IIdi 20280 Boul Henri-bourassa, Quebec, QC G2M 1K9 2004-12-08
Institute for Rehabilitation Research and Development 1504-505 Smyth Road, Ottawa, ON K1H 8M2 2000-08-17
Institut Sud-atlantique De DÉveloppement "isad" 1200 Blvd. Orleans, Gloucester, ON K1C 2W1 1999-02-15
Institut Canadien Pour La Formation Et Le DÉveloppement Autochtones 1455 De Maisonneuve West, Montreal, QC H3G 1M8 1994-12-08
Canadian Institute for Knowledge Development On Middle East and Africa 57 Rue De Pergame, Gatineau, QC J9J 1K2 2017-09-29
The Canadian Institute for The Study of Child Development 3500 De Maisonneuve Boulevard West, Suite 900, Montreal, QC H3Z 3C1 2000-03-07
Institut International Du DÉveloppement Durable 111 Lombard Avenue, Suite 325, Winnipeg, MB R3B 0T4 1990-03-15
Institute for The Development of Democracy and Media (iddm) 730, Rue Mceachran, Outremont, QC H2V 3C7 1994-10-07

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on L'INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DU QUÉBEC.

Dataset Information

Data Provider Corporations Canada
Jurisdiction Canada

This dataset includes 999 thousand corporation entities registered with Corporations Canada, a division of Innovation, Science and Economic Development Canada. Each corporation is registered with corporation number, corporate name, office address, current status, directors, annual filling dates, etc.